-
MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH - Steinhof 65, 40699 Erkrath, Germany
Company Information
- Company registration number
- HRB21240 WUPPERTAL
- Company Status
- LIVE
- Country
- Germany
- Registered Address
- Steinhof 65
- 40699 Erkrath Steinhof 65, 40699 Erkrath DE
Management
- Managing Directors
- Inc Amerika (Geschaeftsfuehrer)
- Claas Jorde (Geschaeftsfuehrer)
- Company secretaries
- Matthias Klemme (Prokura)
- Christoph Manfred Schneider (Prokura)
- Oliver Kaiser (Prokura)
- Manfred Mitze (Prokura)
- Christian Busch (Prokura)
- Daniel Schweizer (Prokura)
Company Details
- Type of Business
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Incorporated
- 2008-07-16
- Dissolved on
- -
- Age Of Company 2008-07-16 15 years
Ownership
- Share Capital
- 540.000,00 EUR
Jurisdiction Particularities
- Additional Status Details
- aktuell
- Court
- DE/Wuppertal
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 529900U7OUKOIN7M0395
- VAT Number
- DE121648163
- Website
- www.mae-group.com
- email address
- sales@mae-group.com
- Phone
- +49 211924830
- Fax
- +49 2119248352
-
MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH Company Description
- MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH is a Gesellschaft mit beschränkter Haftung registered in Germany with the Company reg no HRB21240 WUPPERTAL. Its current trading status is "live". It was registered 2008-07-16. and 6 secretaries. The managing director is Inc Amerika,Claas Jorde.It can be contacted at Steinhof 65 by phone on +49 211924830 by email at sales@mae-group.com by fax on +49 2119248352 on the web at www.mae-group.com.
Get MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH Register ReportShareholder ListArticles of AssociationAnnual AccountChronological Extract
You are here: Mae Maschinen- Und Apparatebau Götzen Gmbh - Steinhof 65, 40699 Erkrath, Germany
- 2008-07-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- years
-
Announcements from the Handelsregister
- 2022-03-03 Modification
- HRB *: MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH, Steinhof *, D-* Erkrath. Prokura erloschen: Klemme, Matthias, Viersen, **. *.*; Schneider, Christoph Manfred, Düsseldorf, **.*.*. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Busch, Christian, Meerbusch, **.*.*; Schweizer, Daniel, Essen, **.*.*.
-
MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH
Did you know? kompany provides original and official company documents for MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH as filed with the government register. Guaranteed.
Register Report
Official proof of the company existence
Shareholder List
Details on the shareholders
Articles of Association
Founding documents
Annual Account
Financial data for the last reported full year
Chronological Extract
Full record of registrable changes
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2018
-
2018-11-16 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 16.11.2018
-
2018-10-09 - Anmeldung vom 09.10.2018
-
2018-12-03 - Anmeldung vom 03.12.2018
-
2018-01-08 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 08.01.2018
-
2018-01-11 - Anmeldung vom 11.01.2018
keyboard_arrow_right 2017
-
2017-06-28 - Anmeldung vom 28.06.2017
keyboard_arrow_right 2015
-
2015-02-03 - Anmeldung vom 03.02.2015
-
2015-02-05 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 05.02.2015
-
2015-01-30 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 30.01.2015
keyboard_arrow_right 2014
-
2014-08-28 - Anmeldung vom 28.08.2014
-
2014-06-05 - Anmeldung vom 05.06.2014
-
2014-04-07 - Anmeldung vom 07.04.2014
-
2014-07-28 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 28.07.2014
-
2014-08-28 - Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 28.08.2014
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-03-08 - Anmeldung vom 08.03.2013
-
2013-02-26 - Anmeldung vom 26.02.2013
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-01-10 - Anmeldung vom 10.01.2012
-
2012-01-10 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 10.01.2012
-
2012-12-13 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 13.12.2012
-
2012-01-10 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 10.01.2012
-
2012-12-13 - Anmeldung vom 13.12.2012
keyboard_arrow_right 2010
-
2010-11-05 - Anmeldung vom 05.11.2010
-
2010-11-05 - Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 05.11.2010
-
2010-09-02 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 02.09.2010
-
2010-11-05 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 05.11.2010
keyboard_arrow_right 2008
-
2008-08-21 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 21.08.2008
-
2008-07-11 - Anmeldung vom 11.07.2008
-
2008-08-21 - Bericht - Werthaltigkeitsnachweis vom 21.08.2008
-
2008-08-21 - Liste der Übernehmer vom 21.08.2008
-
2008-07-11 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 11.07.2008
-
2008-07-11 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 11.07.2008
-
2008-07-11 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 11.07.2008
-
2008-08-21 - Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 21.08.2008
-
2008-08-21 - Anmeldung vom 21.08.2008
-
2008-08-21 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 21.08.2008
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-08-23 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 23.08.2007