-
-
Faiveley Transport Bochum GmbH - Sophie-Opel-Straße 20, 44803 Bochum, Germany
Company Information
- Company registration number
- HRB11587 BOCHUM
- Company Status
- LIVE
- Country
- Germany
- Registered Address
- Sophie-Opel-Straße 20
- 44803 Bochum Sophie-Opel-Straße 20, 44803 Bochum DE
Management
- Managing Directors
- Christopher Antes (Geschaeftsfuehrer)
- Company secretaries
- Frank Friedrich Kreimendahl (Prokura)
- Denis Besevic (Prokura)
- Frank Johannförster (Prokura)
- Susanne Fiorentiono (Prokura)
Company Details
- Type of Business
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Incorporated
- 2008-03-14
- Dissolved on
- -
- Age Of Company 2008-03-14 17 years
Ownership
- Share Capital
- 600.000,00 EUR
Jurisdiction Particularities
- Additional Status Details
- aktuell
- -
- -
- Court
- DE/Bochum
- Email address
- [email protected]
- Phone
- +49 230227750
- Fax
- +49 230227759301
-
Faiveley Transport Bochum GmbH Company Description
- +49 230227759301 .
Get Faiveley Transport Bochum GmbH Register ReportShareholder ListArticles of AssociationAnnual AccountChronological Extract
You are here: Faiveley Transport Bochum Gmbh - Sophie-Opel-Straße 20, 44803 Bochum, Germany
- 2008-03-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- years
-
Announcements from the Handelsregister
- 2024-06-14 Modification
- Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § * Absatz * UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
-
Faiveley Transport Bochum GmbH
Did you know? kompany provides original and official company documents for Faiveley Transport Bochum GmbH as filed with the government register. Guaranteed.
Register Report
Official proof of the company existence
Shareholder List
Details on the shareholders
Articles of Association
Founding documents
Annual Account
Financial data for the last reported full year
Chronological Extract
Full record of registrable changes
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2021
-
2021-03-15 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 15.03.2021
-
2021-04-12 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 12.04.2021
-
2021-04-07 - Anmeldung vom 07.04.2021
-
2021-06-01 - Anmeldung vom 01.06.2021
-
2021-03-15 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 15.03.2021
keyboard_arrow_right 2020
-
2020-11-12 - Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 12.11.2020
-
2020-05-26 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 26.05.2020
-
2020-11-03 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 03.11.2020
-
2020-12-01 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 01.12.2020
-
2020-10-13 - Anmeldung vom 13.10.2020
-
2020-12-09 - Anmeldung vom 09.12.2020
keyboard_arrow_right 2019
-
2019-07-17 - Anmeldung vom 17.07.2019
keyboard_arrow_right 2018
-
2018-02-27 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 27.02.2018
-
2018-06-06 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 06.06.2018
-
2018-07-04 - Anmeldung vom 04.07.2018
-
2018-09-17 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 17.09.2018
-
2018-01-10 - Anmeldung vom 10.01.2018
keyboard_arrow_right 2017
-
2017-03-23 - Anmeldung vom 23.03.2017
keyboard_arrow_right 2016
-
2016-12-09 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 09.12.2016
-
2016-01-07 - Anmeldung vom 07.01.2016
-
2016-06-29 - Anmeldung vom 29.06.2016
-
2016-08-02 - Anmeldung vom 02.08.2016
-
2016-12-09 - Anmeldung vom 09.12.2016
-
2016-12-09 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 09.12.2016
keyboard_arrow_right 2015
-
2015-04-24 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 24.04.2015
-
2015-02-05 - Anmeldung vom 05.02.2015
-
2015-06-01 - Anmeldung vom 01.06.2015
keyboard_arrow_right 2014
-
2014-04-08 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 08.04.2014
-
2014-09-25 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 25.09.2014
-
2014-05-21 - Anmeldung vom 21.05.2014
-
2014-07-18 - Anmeldung vom 18.07.2014
-
2014-10-10 - Anmeldung vom 10.10.2014
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-06-24 - Anmeldung vom 24.06.2013
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-08-31 - Anmeldung vom 31.08.2012
keyboard_arrow_right 2011
-
2011-09-29 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 29.09.2011
-
2011-05-11 - Anmeldung vom 11.05.2011
-
2011-07-14 - Anmeldung vom 14.07.2011
-
2011-08-23 - Anmeldung vom 23.08.2011
-
2011-10-07 - Anmeldung vom 07.10.2011
keyboard_arrow_right 2010
-
2010-03-22 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 22.03.2010
-
2010-07-06 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 06.07.2010
-
2010-04-22 - Anmeldung vom 22.04.2010
-
2010-07-14 - Anmeldung vom 14.07.2010
keyboard_arrow_right 2009
-
2009-10-16 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 16.10.2009
-
2009-11-27 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 27.11.2009
-
2009-07-21 - Anmeldung vom 21.07.2009
-
2009-10-23 - Anmeldung vom 23.10.2009
-
2009-12-10 - Anmeldung vom 10.12.2009
keyboard_arrow_right 2008
-
2008-05-14 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 14.05.2008
-
2008-10-30 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 30.10.2008
-
2008-04-02 - Anmeldung vom 02.04.2008
-
2008-06-02 - Anmeldung vom 02.06.2008
-
2008-09-10 - Anmeldung vom 10.09.2008
-
2008-11-10 - Anmeldung vom 10.11.2008
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-11-12 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 12.11.2007
-
2007-12-06 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 06.12.2007
-
2007-12-10 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 10.12.2007
-
2007-11-20 - Anmeldung vom 20.11.2007
-
2007-12-10 - Anmeldung vom 10.12.2007
-
2007-12-10 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 10.12.2007